Our Family History


Print Bookmark

Leavitt

Male 1903 - 1903  (0 years)


Generations:      Standard    |    Vertical    |    Compact    |    Box    |    Text    |    Ahnentafel    |    Fan Chart    |    Media    |    PDF

 1. Leavitt 
 B: 4 May 1903 
 P:  Parsonsfield, York, Maine 
 D: 4 May 1903 
 P:  Parsonsfield, York, Maine 
 2. Edwin A. Leavitt 
 B: 24 Dec 1869 
 P:  Effingham, Carroll, New Hampshire 
 M: 24 Dec 1892 
 P:  Parsonsfield, York, Maine 
 D: 2 Sep 1930 
 P:  Parsonsfield, York, Maine 
 4. Edward P. Leavitt 
 B: 2 Jul 1818 
 P:  Ripley, Somerset, Maine 
 M: 12 Oct 1859 
 P:  of, Penobscot, Maine 
 D: 3 Jan 1887 
 P:  Parsonsfield, York, Maine 
 8. Edward Leavitt  =>
 B: 20 Jun 1759 
 P:  Wakefield, Carroll, New Hampshire 
 M: 28 Jan 1818 
 P:  Rochester, Strafford, New Hampshire 
 D: 25 Jul 1831 
 P:  Ripley, Somerset, Maine 
 9. Abigail Copp 
 B: 1781 
 P:  Tuftonboro Twp, Carroll, New Hampshire 
 D: 11 Sep 1858 
 P:  Tuftonboro Twp, Carroll, New Hampshire 
 5. Ruth A Peavey 
 B: 30 Jul 1833 
 P:  Stetson, Penobscot, Maine 
 D: 4 Jun 1892 
 P:  Bangor, Penobscot, Maine 
 10. Edmund Peavey 
 B: Abt 1801 
 P:  of, Penobscot, Maine 
 M: 9 Jun 1825 
 P:  Exeter, Penobscot, Maine 
 D: Yes, date unknown 
 P:   
 11. Sabra Jones 
 B: Abt 1805 
 P:  of, Penobscot, Maine 
 D: Yes, date unknown 
 P:   
 3. Josephine Winifred Haynes 
 B: 18 Jun 1876 
 P:  Parsonsfield, York, Maine 
 D: 4 Jun 1923 
 P:   
 6. Joseph Emery Haynes 
 B: 10 Apr 1838 
 P:  South Parsonsfield, York, Maine 
 M: 23 Oct 1877 
 P:  Parsonsfield, York, Maine 
 D: 27 Feb 1891 
 P:  Parsonsfield, York, Maine 
 12.  
   
   
   
   
   
   
 13.  
   
   
   
   
 7. Ada Beatrice Coldwell 
 B: Nov 1857 
 P:  , Kings, Nova Scotia, Canada 
 D: 12 May 1906 
 P:  Parsonsfield, York, Maine 
 14.  
   
   
   
   
   
   
 15.  
   
   
   
   

This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.1, written by Darrin Lythgoe 2001-2024.